Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Livingston County (Kentucky)

Lage des Livingston County in Kentucky

Die Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Livingston County in Kentucky führt die Bauwerke und historischen Stätten im Livingston County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.[1]

[2] Name[3] Bild Eintragsdatum Lage Ort Beschreibung
1 Fort Star
Fort Star
Fort Star
1998
ID-Nr. 98000938
Rund 500 m südlich von Smithland
37° 8′ 2″ N, 88° 24′ 5″ W37.133889-88.401389
Smithland
2 Gower House
Gower House
Gower House
1973
ID-Nr. 73000815
Water Street
37° 8′ 37″ N, 88° 24′ 17″ W37.143611-88.404722
Smithland
3 Thomas Lawson House
Thomas Lawson House
Thomas Lawson House
1978
ID-Nr. 78001378
Wabash Avenue
37° 0′ 14″ N, 88° 14′ 11″ W37.003889-88.236389
Grand Rivers
4 Livingston County Courthouse and Clerk's Offices
Livingston County Courthouse and Clerk's Offices
Livingston County Courthouse and Clerk's Offices
2011
ID-Nr. 11000794
351 Court Street
37° 8′ 22″ N, 88° 24′ 16″ W37.139444-88.404444
Smithland
5 Mantle Rock Archeological District
Mantle Rock Archeological District
Mantle Rock Archeological District
2004
ID-Nr. 04001253
KY 133
37° 21′ 10″ N, 88° 25′ 41″ W37.352778-88.428056
Smithland
6 Masonic Hall-Federal Commissary Building
Masonic Hall-Federal Commissary Building
Masonic Hall-Federal Commissary Building
1998
ID-Nr. 98000939
Main Street Ecke Charlotte Street
37° 8′ 25″ N, 88° 24′ 24″ W37.140278-88.406667
Smithland
7 Richard Olive House
Richard Olive House
Richard Olive House
1982
ID-Nr. 82002732
Court Street
37° 8′ 22″ N, 88° 24′ 14″ W37.139444-88.403889
Smithland

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Auszug aus dem National Register of Historic Places – Livingston County Abgerufen am 6. September 2012
  2. Die Nummerierung in dieser Listenspalte ist an der vom National Park Service vorgelegten Reihenfolge der Einträge orientiert; die Farben unterscheiden verschiedene Schutzgebietstypen des Nationalparksystems mit landesweiter Bedeutung (z. B. National Historic Landmarks) von den sonstigen Einträgen im National Register of Historic Places.
  3. National Register Information System. In: National Register of Historic Places. National Park Service, abgerufen am 9. Juli 2010 (englisch). 
Einträge im National Register of Historic Places in Kentucky

National Register of Historic Places in Kentucky

Adair | Allen | Anderson | Ballard | Barren | Bath | Bell | Boone | Bourbon | Boyd | Boyle | Bracken | Breathitt | Breckinridge | Bullitt | Butler | Caldwell | Calloway | Campbell | Carlisle | Carroll | Carter | Casey | Christian | Clark | Clay | Clinton | Crittenden | Cumberland | Daviess | Edmonson | Elliott | Estill | Fayette | Fleming | Floyd | Franklin | Fulton | Gallatin | Garrard | Grant | Graves | Grayson | Green | Greenup | Hancock | Hardin | Harlan | Harrison | Hart | Henderson | Henry | Hickman | Hopkins | Jackson | Jefferson | Jessamine | Johnson | Kenton | Knott | Knox | LaRue | Laurel | Lawrence | Lee | Leslie | Letcher | Lewis | Lincoln | Livingston | Logan | Lyon | Madison | Magoffin | Marion | Marshall | Martin | Mason | McCracken | McCreary | McLean | Meade | Menifee | Mercer | Metcalfe | Monroe | Montgomery | Morgan | Muhlenberg | Nelson | Nicholas | Ohio | Oldham | Owen | Owsley | Pendleton | Perry | Pike | Powell | Pulaski | Robertson | Rockcastle | Rowan | Russell | Scott | Shelby | Simpson | Spencer | Taylor | Todd | Trigg | Trimble | Union | Warren | Washington | Wayne | Webster | Whitley | Wolfe | Woodford